The RoyalGazette
FrederictonNew Brunswick
Gazetteroyale
FrederictonNouveau-Brunswick
Vol. 173 Wednesday, May 13, 2015 / Le mercredi 13 mai 2015 587
ISSN 1714-9428
Notice to Readers
The Royal Gazette is officially published on-line.
Except for formatting, documents are published in TheRoyal Gazette as submitted.
Material submitted for publication must be received bythe Royal Gazette Coordinator no later than noon, at leastseven working days prior to Wednesday’s publication.However, when there is a public holiday, please contactthe Royal Gazette Coordinator at 453-8372.
APRIL 2, 20152015-65
Under paragraph 5(2)(a) of the Interpretation Act and subsec-tion 20.1(1) of the Workplace Health, Safety and CompensationCommission and Workers’ Compensation Appeals TribunalAct, and notwithstanding subsection 20.1(2) of the WorkplaceHealth, Safety and Compensation Commission and Workers’Compensation Appeals Tribunal Act, the Lieutenant-Governorin Council appoints J. Richard Hatchette, Saint John, NewBrunswick, as Interim Chairperson of the Workers’ Compensa-tion Appeals Tribunal for a term of sixty days, effective April 2,2015.
Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor
________________
Orders in Council
Avis aux lecteurs
La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne.
Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dansla Gazette royale tels que soumis.
Les documents à publier doivent parvenir à la coordon-natrice de la Gazette royale, à midi, au moins sept joursouvrables avant le mercredi de publication. En cas de jourférié, veuillez communiquer avec la coordonnatrice de laGazette royale au 453-8372.
LE 2 AVRIL 20152015-65
En vertu de l’alinéa 5(2)a) de la Loi d’interprétation et du para-graphe 20.1(1) de la Loi sur la Commission de la santé, de la sé-curité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribu-nal d’appel des accidents au travail, et nonobstant leparagraphe 20.1(2) de la Loi sur la Commission de la santé, dela sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et leTribunal d’appel des accidents au travail, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme J. Richard Hatchette, de SaintJohn (Nouveau-Brunswick), président intérimaire du Tribunald’appel des accidents au travail, pour un mandat de soixantejours, à compter du 2 avril 2015.
La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau
________________
Décrets en conseil
The Royal Gazette — May 13, 2015 588 Gazette royale — 13 mai 2015
APRIL 2, 20152015-67
Under paragraph 5(2)(a) of the Interpretation Act and subsec-tion 20.1(1) and 20.1(3) of the Workplace Health, Safety andCompensation Commission and Workers’ Compensation Ap-peals Tribunal Act, the Lieutenant-Governor in Council ap-points the following persons as Vice-Chairpersons of the Work-ers’ Compensation Appeals Tribunal for a term of three years,effective April 2, 2015:
(a) Shelley R. Dumouchel, Fredericton, New Brunswick;
(b) J. Richard Hatchette, Saint John, New Brunswick;
(c) Jennifer Cleversey Moffitt, Bathurst, New Brunswick;
(d) Denyse Hélène Landry, Grande-Anse, New Brunswick;
(e) Anik Bossé, Edmundston, New Brunswick; and(f) Candace R. Salmon, Moncton, New Brunswick.
Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor
LE 2 AVRIL 20152015-67
En vertu de l’alinéa 5(2)a) de la Loi d’interprétation et des pa-ragraphes 20.1(1) et 20.1(3) de la Loi sur la Commission de lasanté, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au tra-vail et le Tribunal d’appel des accidents au travail, lelieutenant-gouverneur en conseil nomme les personnes sui-vantes vice-présidentes du Tribunal d’appel des accidents autravail, pour un mandat de trois ans, à compter du 2 avril 2015 :
a) Shelley R. Dumouchel, de Fredericton (Nouveau-Brunswick);b) J. Richard Hatchette, de Saint John (Nouveau-Brunswick);c) Jennifer Cleversey Moffitt, de Bathurst (Nouveau-Brunswick);d) Denyse Hélène Landry, de Grande-Anse (Nouveau-Brunswick);e) Anik Bossé, d’Edmundston (Nouveau-Brunswick); etf) Candace R. Salmon, de Moncton (Nouveau-Brunswick).
La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau
FONDS RÉGIONALE D’INVESTISSEMENT KEDGWICK INC.
Kedgwick 681430 2015 03 11
681751 N.B. LTD. / 681751 N.-B. LTÉE Fredericton 681751 2015 03 28
Chess Copyright International Inc. Fredericton 682006 2015 04 10
Dynamic Health Physiotherapy P.C. Inc. Moncton 682007 2015 04 10
Calder Enterprises Canada Inc. St. Stephen 682076 2015 04 14
682077 N.B. INC. Moncton 682077 2015 04 14
Wallace Imaging Consulting Inc. Riverview 682078 2015 04 14
FRANK KELEMEN CARPENTRY LTD. Barnesville 682079 2015 04 14
682081 NB Inc. Woodstock 682081 2015 04 14
682083 NB INC. Hanwell 682083 2015 04 15
682088 NB Ltée 682088 N.B. Ltd. Haut-Sheila 682088 2015 04 15
Canada Property Manager GP Inc. Fredericton 682093 2015 04 15
InStorage Property Manager GP Inc. Fredericton 682094 2015 04 15
TKG-StorageMart Partners Canada Mezzanine GP Inc. Fredericton 682096 2015 04 15
TKG-StorageMart Partners Canada Portfolio GP Inc. Fredericton 682097 2015 04 15
Loi sur les corporations commercialesBusiness Corporations Act
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of incorporation has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commer-ciales, un certificat de constitution en corporation a été émis à :
ReferenceNumber Date
Registered Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour
The Royal Gazette — May 13, 2015 589 Gazette royale — 13 mai 2015
EUROSTAR WINDOWS AND DOORS INC. Richibucto 682098 2015 04 15
682099 NB LTD. Lower St. Marys 682099 2015 04 15
JMR ENTERPRISE INC. Bouctouche 682101 2015 04 15
BGA MECHANICAL SERVICES LTD. Moncton 682103 2015 04 15
CON-MIX CONSULTING LTD. Scotch Settlement 682114 2015 04 16
682115 NB Ltd. Lower Greenwich 682115 2015 04 16
682117 N.B. INC. Fredericton 682117 2015 04 16
PIÈCES D’AUTO SAVOIE LANGLOIS LTÉE Saint-Quentin 682118 2015 04 16
The Bra Room Ltd. Rothesay 682119 2015 04 16
682121 N.B. Inc.682121 N.-B. Inc. Dieppe 682121 2015 04 16
682122 NB Corp. South Tetagouche 682122 2015 04 16
The Sour Grape Inc. Oromocto 682123 2015 04 16
JAAM Fisheries Inc. Stuart Town 682124 2015 04 16
KSJ FOOD PROCESSING LTD. Moncton 682127 2015 04 16
A.B.L.E. HOMECARE INC. Seeleys Cove 682129 2015 04 16
TIME AND TIDE II FISHERIES INC. Fairhaven 682131 2015 04 16
GARDERIE CABOTIN LTÉE Tracadie-Sheila 682134 2015 04 16
JLHIM Properties Inc. Rothesay 682135 2015 04 16
PROJECTS PLUS INC. Rothesay 682136 2015 04 16
Russell Holdings Inc. Grand Manan 682137 2015 04 16
Evans and Associates Educational Consulting Ltd. Fredericton 682138 2015 04 16
682140 NB Ltd. Saint John 682140 2015 04 16
Knight Moves Fisheries Inc. White Head 682141 2015 04 16
682144 NB Inc. Moncton 682144 2015 04 17
682145 NB INC. Haut-Lamèque 682145 2015 04 17
Future Forest Music & Arts Festival Inc. Fredericton 682146 2015 04 17
682147 N.B. Ltd. Saint John 682147 2015 04 17
682149 NB Inc. Moncton 682149 2015 04 17
Black Arcs Inc. Fredericton 682150 2015 04 17
MALLAIS LAVE-AUTO INC. Tracadie-Sheila 682153 2015 04 17
MWC Farms Ltd. Jacksonville 682161 2015 04 17
Dr. Christopher Gallant P.C. Inc. Moncton 682162 2015 04 17
DJ Tree Cutting Inc. Sainte-Louise 682171 2015 04 18
Cogswell & Saunders Conference and Event Planners Ltd. Hanwell 682172 2015 04 18
Offbeat Homes Inc. Fredericton 682173 2015 04 18
StopCold Laser Saint John Inc. Moncton 682175 2015 04 19
682178 N.B. Ltd. Long Reach 682178 2015 04 20
The Royal Gazette — May 13, 2015 590 Gazette royale — 13 mai 2015
Akova Holdings Limited Fredericton 682183 2015 04 20
1Source Commercial Financing Inc. Saint John 682184 2015 04 20
Kelly Auto Glass (2015) Ltd. Miramichi 682185 2015 04 20
RITCHIE’S TRUCK AND TRAILER REPAIR LTD. Bristol 682186 2015 04 20
BRIEN INVESTCO LTD. Moncton 682187 2015 04 20
682188 NB INC. Canobie 682188 2015 04 20
PrimusWebsite inc. Dieppe 682191 2015 04 20
KASSCO Construction Ltd. Saint John 682192 2015 04 20
L’ÉRABLIÈRE BF INC Saint-François-de-Madawaska 682193 2015 04 20
DRUIDES DU WEB INC. Moncton 682195 2015 04 20
Gauvin Installation Finition Ltée Paquetville 682196 2015 04 20
Buckland Merrifield Gallery Inc. Saint John 682200 2015 04 20
682201 N.B. Ltd. Miramichi 682201 2015 04 20
Full Blast Pressure Washing & More Inc. Notre-Dame 682202 2015 04 20
Groupe117 Inc. Baie-Sainte-Anne 682210 2015 04 21
AWL ENTERPRISES LTD. Quispamsis 682213 2015 04 21
Konsulati, Inc. Fredericton 682214 2015 04 21
York Electric Inc. Beardsley 682219 2015 04 21
Peter R. Forestell Professional Corporation Saint John 682220 2015 04 21
Peter R. Forestell PC Inc. Saint John 682223 2015 04 21
Jemix Technology Inc. Saint John 682224 2015 04 21
Impressive Homes & Designs Inc. Nackawic 682231 2015 04 22
Branded Trucking Inc. Skiff Lake 682232 2015 04 22
682235 NB INC. Hanwell 682235 2015 04 22
O’CEILTEACHS BLUEBERRY FARMING INC. Petit-Tracadie 682237 2015 04 22
682245 NB Inc. Saint John 682245 2015 04 22
Jackson’s Harbour Limited Upper Hainesville 682246 2015 04 22
682249 NB Inc. Village-des-Poirier 682249 2015 04 22
Aimeily Beauty Care Ltd. Rothesay 682254 2015 04 22
RV COUNTRY LTD. Bloomfield Ridge 682255 2015 04 22
Josh McElman Professional Corporation Saint John 682256 2015 04 22
Platinum DFX Inc. Dieppe 682257 2015 04 22
Josh McElman PC Inc. Saint John 682258 2015 04 22
682259 N.-B. Inc. Grande-Digue 682259 2015 04 22
Ace Ventures Inc. Fredericton 682263 2015 04 22
PAW & KIDS TRUCKING LTD. Avondale 682267 2015 04 23
SUPERIOR LIVING SPACES INC. Moncton 682268 2015 04 23
The Royal Gazette — May 13, 2015 591 Gazette royale — 13 mai 2015
Velocity Solutions Corp. Berry Mills 682269 2015 04 23
Altaris Group Inc. Riverview 682270 2015 04 23
Bakam Maintenance Inc. Moncton 682272 2015 04 23
M.E.L. Trucking Inc. Tracadie-Sheila 682273 2015 04 23
682274 NB Inc. Moncton 682274 2015 04 23
682275 NB CORP. Fredericton 682275 2015 04 23
682276 N.B. Inc. Miramichi 682276 2015 04 23
Global KnoVac Inc. Saint Andrews 682277 2015 04 23
PT Health NB 2015 Professional Corporation Inc. Moncton 682287 2015 04 23
682289 NB Inc. Saint-Quentin 682289 2015 04 23
TLC Home Reno Ltd. Dieppe 682291 2015 04 23
682292 NB INC. Dalhousie 682292 2015 04 23
_____________________________________________________
Alexa Smith Medicine Professional Corporation Inc. Rothesay Nouvelle-Écosse /Nova Scotia
682106 2015 04 16
_____________________________________________________
JEAN B. BASTARACHE CO. LTD 001484 2015 04 23
SCOTT TARGETT GROUP INC. 056738 2015 04 16
058809 N.B. INC. 058809 2015 04 23
PECHERIES REJEAN N. LTEE 058965 2015 04 22
Basque Construction Ltée/Basque Construction Ltd 609703 2015 04 16
648830 NEW BRUNSWICK INCORPORATED 648830 2015 04 23
RSLD FOODS INC. 661044 2015 04 23
Islandview Holdings Inc. 681457 2015 04 17
_____________________________________________________
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpo-rations Act, a certificate of continuance has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de prorogation a été émis à :
Previous ReferenceJurisdiction Number Date
Registered Office Compétence Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré antérieure référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification a été émis à :
DateReference Number Year Month Day
Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour
The Royal Gazette — May 13, 2015 592 Gazette royale — 13 mai 2015
509046 NB Inc. CAFÉ COGNITO INCORPORATED 509046 2015 04 21
Ted Kelly Auto Glass and Sales Ltd. 654205 NB INC. 654205 2015 04 21
Le Depanneur De Sainte-Rose Inc. Pièces Parts Expert Inc. 662167 2015 04 23
Covalent Enterprises Ltd. 673969 NB Inc. 673969 2015 04 16
Central & Eastern Transport Corp. 676712 NB LTD. 676712 2015 04 21
EXPERIENTIAL DEA INC. Experiential Digital Engagement Agency Inc. 681782 2015 04 22
East Coast Cycle Ltée/Ltd. 681665 N.B. Inc. 682065 2015 04 10
_____________________________________________________
681665 N.B. Inc. EAST COAST CYCLE LTD./LTEE681665 N.B. Inc.
Shediac Bridge 682065 2015 04 10
_____________________________________________________
665929 NB Inc. Edmundston 665929 2015 04 08
_____________________________________________________
TAYLOR PETROLEUM (1985) LTD. Canada 035156 2015 03 31
_____________________________________________________
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment which includes a change inname has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification contenant un changement de raisonsociale a été émis à :
DatePrevious name Reference Number Year Month Day
Name / Raison sociale Ancienne raison sociale Numéro de référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amalgamation has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de fusion a été émis à :
ReferenceNumber Date
Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Registered Office Numéro de Year Month DayCorporation issue de la fusion Corporations fusionnantes Bureau enregistré référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of dissolution has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de dissolution a été émis à :
ReferenceNumber Date
Registered Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of discontinuance has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de cessation a été émis à :
DateJurisdiction of Continuance Reference Number Year Month Day
Name / Raison sociale Compétence de prorogation Numéro de référence année mois jour
The Royal Gazette — May 13, 2015 593 Gazette royale — 13 mai 2015
CAIN SURVEYS LTD. 020497 2015 04 02
OLA VIENNEAU POTATO PRODUCER LIMITED 050266 2015 04 22
C. HALL HEAVY EQUIPMENT REPAIR LTD. 057176 2015 04 14
HARVEY GAS BAR (1995) LTD. 501245 2015 04 20
KENT PREMIUM FINANCE INC. 513772 2015 04 14
515038 N.B. LTD. 515038 2015 04 16
EVOLUTION: CONSTRUCTIVE SOLUTIONS INC. 618513 2015 04 13
Roach Management Co. Ltd. 635818 2015 04 14
YOGA HAUS LTD. 662085 2015 04 13
_____________________________________________________
9225-4002 QUÉBEC INC. Québec / Quebec M. Gilles BrineShediac
681824 2015 04 01
Impak media solution inc. Québec / Quebec Martin TremblayBeresford
682034 2015 04 20
Osprey Land Services Inc. Canada Willard M. JenkinsSaint John
682058 2015 04 14
J.P. MORGAN SECURITIES CANADA INC. / J.P. MORGAN VALEURS MOBILIÈRES CANADA INC.
Canada Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John
682086 2015 04 15
LIQUIDS IN MOTION LTD. Alberta Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John
682087 2015 04 15
BROOKFIELD GLOBAL INTEGRATED SOLUTIONS CANADA GP LTD./BROOKFIELD SOLUTIONS GLOBALES INTÉGRÉESCANADA GP LTÉE
Ontario Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John
682157 2015 04 17
_____________________________________________________
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of revival has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de reconstitution a été émis à :
DateReference Number Year Month Day
Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of registration of extra-provincial corporationhas been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat d’enregistrement de corporation extraprovinciale a étéémis à :
ReferenceNumber Date
Jurisdiction Agent and Address Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence Représentant et adresse référence année mois jour
The Royal Gazette — May 13, 2015 594 Gazette royale — 13 mai 2015
Brookfield Global IntegratedSolutions Realty Inc.Société Immobilière BrookfieldSolutions Globales Intégrées Inc.
Brookfield Johnson ControlsRealty Inc.Société Immobilière BrookfieldContrôles Johnson Inc.
611140 2015 04 20
MARRIOTT HOTELS OF CANADA ULC Marriott Hotels of Canada Ltd. 632376 2015 04 21
_____________________________________________________
LUXURY HOTELS INTERNATIONAL OF CANADA, ULC
MARRIOTT HOTELS OF CANADA ULC
Deborah M. PowerFredericton
681772 2015 04 21
ITW CANADA INC. ITW CANADA INC. Arthur T. DoyleSaint John
682107 2015 04 16
BHP BILLITON CANADA INC. BHP BILLITON CANADA INC. Franklin O. LegerSaint John
682166 2015 04 17
TIBBETT & BRITTEN GROUP CANADA INC.
TIBBETT & BRITTEN GROUP CANADA INC.
Willard M. JenkinsSaint John
682167 2015 04 17
ARCADIS CANADA INC. ARCADIS Canada, Inc. Stewart McKelveyCorporate Services (NB) Inc.Saint John
682179 2015 04 20
Fairmont Hotels Inc.Hôtels Fairmont Inc.
Fairmont Hotels Inc.Hôtels Fairmont Inc.
Stewart McKelveyCorporate Services (NB) Inc.Saint John
682180 2015 04 20
Nashwaak Valley ATV Club Inc. Richibucto Road 682009 2015 04 10
CPL. Shari Irving Memorial Foundation Inc. St. Stephen 682036 2015 04 13
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment of registration of extra-provincial corporation has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification de l’enregistrement de corporationextraprovinciale a été émis à :
ReferenceNumber Date
Previous name Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Ancienne raison sociale référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of registration of amalgamated corporationhas been issued to the following extra-provincial corporations:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat d’enregistrement d’une corporation extraprovincialeissue de la fusion a été émis aux corporations extraprovinciales sui-vantes :
ReferenceAgent and Address Number Date
Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Représentant et Numéro de Year Month DayCorporation issue de la fusion Corporations fusionnantes adresse référence année mois jour
Loi sur les compagniesCompanies ActPUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,
letters patent have been granted to:SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettres
patentes ont été émises à :
ReferenceNumber Date
Head Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Siège social référence année mois jour
The Royal Gazette — May 13, 2015 595 Gazette royale — 13 mai 2015
Kennebecasis Valley Oasis Youth Centre Inc. Quispamsis 682105 2015 04 16
Le Grand Défi des Héros du Coeur Inc. / The Great Challenge,Heroes of the Heart Inc.
Shediac 682111 2015 04 16
PET N.B. South Canada Ltd. St. Stephen 682128 2015 04 16
ACADÉMIE DU LEADERSHIP DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC. Balmoral 682189 2015 04 20
_____________________________________________________
THE YOUNG WOMEN’S CHRISTIAN ASSOCIATION OF MONCTON 097674 2015 04 22
Hillsdale Baptist Church Committee Incorporated 680529 2015 04 13
_____________________________________________________
Knights of Columbus Council 6595 Properties Incorporated
COUNCIL 6595 HOLDINGS INC. 658839 2015 04 15
_____________________________________________________
Revue acadienne de création littéraire Inc. 616344 2015 04 15
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,supplementary letters patent have been granted to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettrespatentes supplémentaires ont été émises à :
DateReference Number Year Month Day
Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,supplementary letters patent, which include a change in name,have been granted to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettrespatentes supplémentaires, contenant une nouvelle raison sociale,ont été émises à :
DateNew Name Reference Number Year Month Day
Name / Raison sociale Nouvelle raison sociale Numéro de référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that the charter of the followingcompany is revived under subsection 35.1(1) of the Companies Act:
SACHEZ que la charte de la compagnie suivante est reconstituéeen vertu du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les compagnies :
DateReference Number Year Month Day
Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour
The Royal Gazette — May 13, 2015 596 Gazette royale — 13 mai 2015
Bookstravaganza: A Really Big, Really Good, Really Fun Charity Book Sale
Laubach Literacy NewBrunswick Inc.
Moncton 680600 2015 04 16
East Coast Basketball Academy Damian Gay Rothesay 681413 2015 04 16
Moncton Honda BAIG BLVD. MOTORS INC. Moncton 681436 2015 04 08
Atlantic Land Drafting and Consultants
Justin Christie Waasis 681711 2015 03 26
Marriott Hotels of Canada LUXURY HOTELS INTERNATIONALof Canada, ULC
Fredericton 681773 2015 04 21
Grace Institute of Biblical Theology
International ChristianChurch of Canada, Inc.
Miramichi 681861 2015 04 20
VIC PARK PALE ALE Prince Edward Island Brewing Company Ltd.
Saint John 681900 2015 04 07
SETTING DAY Prince Edward Island Brewing Company Ltd.
Saint John 681901 2015 04 07
RE-ANIMATOR Prince Edward Island Brewing Company Ltd.
Saint John 681902 2015 04 07
BAR ITALIA Boomerang’s Steakhouse N.B. Ltd. Moncton 681944 2015 04 08
LEVEL UP LASER TAG LEVEL UP INVESTMENTS INC. Saint John 681951 2015 04 08
Canada Law Financing 678107 NB Inc. Dieppe 681952 2015 04 08
River Valley Baptist Church Andrew NissleyCarol RideoutJonathan StephensonKimberly Stephenson
McKenzie Corner 681953 2015 04 08
Hillsborough Golf Club 680752 N.B. Inc. Hillsborough 682010 2015 04 17
Nikies Lunch Box 674907 NB INC. Aldouane 682035 2015 04 13
DMP-BBQ Denis Pelletier Edmundston 682037 2015 04 13
WEST SIDE HOME IMPROVEMENTS
Roger C.E. Wilson Saint John 682038 2015 04 13
Dynacare MedAxio Insurance MedicalServices LP
Saint John 682052 2015 04 21
Dynacare Insurance Solutions MedAxio Insurance MedicalServices LP
Saint John 682053 2015 04 21
Dynacare Solutions d’Assurance
MedAxio Insurance MedicalServices LP
Saint John 682054 2015 04 21
Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des
appellations commercialesPartnerships and Business Names
Registration ActPUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and
Business Names Registration Act, a certificate of business name hasbeen registered:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat d’appel-lation commerciale a été enregistré :
Registrant of Address of Business ReferenceCertificate or Agent Number DateEnregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour
The Royal Gazette — May 13, 2015 597 Gazette royale — 13 mai 2015
A. Betts Licensed Carpenter Andrew Betts Meductic 682068 2015 04 14
Bocabec Renewables 633514 N.B. Ltd. Bocabec 682070 2015 04 14
Zoe Construction 681941 N.-B. Ltée Brantville 682071 2015 04 14
JONBOYS HEAT PUMP SERVICES John K. Currie Weldon 682074 2015 04 14
Foran Bed Inspections-FBI Todd Foran Moncton 682091 2015 04 15
Kane’s Lawn and Yard Care Chris Kane Lepreau 682095 2015 04 15
VERTICAL VISIONS VENTURES Terrance Eatmon Saint John 682102 2015 04 15
J.Parker Roofing Josh Parker Fredericton 682104 2015 04 15
Echelon Insurance EGI Financial Holdings Inc. Saint John 682112 2015 04 16
Echelon Assurance EGI Financial Holdings Inc. Saint John 682113 2015 04 16
MAG HOOD PHOTOGRAPHY Maggie Hood Fredericton 682120 2015 04 16
McSweeney Company Dinner Theatre TIDE & BOAR GASTRO PUB INC.
Moncton 682126 2015 04 16
Nashwaak Valley Tire & Muffler Shop
JeanYves Doiron Nashwaak Village 682130 2015 04 16
OK TIRE MONCTON 681723 NB Ltd. Moncton 682132 2015 04 16
Big Red Shoes Sales Michael MacDonald Nauwigeauk 682133 2015 04 16
Memeres Home Care and Education
Jocelyne Bourque Shediac 682142 2015 04 16
KEVIN’S COMPUTER & ELECTRONIC REPAIRS
Kevin Letteney St. Stephen 682143 2015 04 16
DAYLIGHT BREW - MIDNIGHT SNOOZE
Tori Neilson Woodstock 682148 2015 04 17
Michaela’s Pooch Parlor Michaela MacDonald Sippley St. Margarets 682151 2015 04 17
BRIAN TRACY TRAINING & COUCHING SERVICES
Son Thanh Trinh Fredericton 682152 2015 04 17
Brookfield Global Integrated Solutions
BROOKFIELD GLOBALINTEGRATED SOLUTIONSCANADA LP/BROOKFIELDSOLUTIONS GLOBALESINTÉGRÉES CANADA S.E.C.
Saint John 682158 2015 04 17
Sash Sheek Clothing Sasha Diggs Oromocto 682160 2015 04 17
Ye Olde Bank CROSS WATERS TRADE BROKERS LTD.
Belledune 682165 2015 04 17
Shingle Saver Solutions Stephen Kearney Saint John 682174 2015 04 19
Petty Service Centre Patrick McQuinn Petitcodiac 682176 2015 04 19
Travelodge Suites Saint John Holloway Lodging LimitedPartnership
Saint John 682181 2015 04 20
Travelodge Suites Moncton Holloway Lodging LimitedPartnership
Saint John 682182 2015 04 20
RCR Maintenance and Repair Kirby Reid Dieppe 682203 2015 04 20
Maple Street Cleaning Wanda Doherty Chipman 682204 2015 04 20
Parampara Canada General Mills Canada CorporationCorporation General Mills Canada
Saint John 682205 2015 04 21
The Royal Gazette — May 13, 2015 598 Gazette royale — 13 mai 2015
Vienneau bois de chauffage Jacques Vienneau Tremblay 682206 2015 04 21
Maritime Firewood Pierre Cayouette Dieppe 682211 2015 04 21
Selfnessology Self-Help Erika Keirstead Lower Coverdale 682212 2015 04 21
Agrell Marketing James Agrell Nauwigewauk 682218 2015 04 21
Alderic Keith MMA Alderic Keith Riverview 682227 2015 04 21
R.G. Ryan’s Roofing Ryan Gary Gallant Miramichi 682228 2015 04 21
Loopy Wool Supply & Studio Christina Waddy Moncton 682229 2015 04 22
HowWeRoll Painting Services Jared Hartley Riverview 682230 2015 04 22
FRANCIS CORMIER AUTOMOTIVE SOLUTIONS
Francis Cormier Memramcook 682233 2015 04 22
DANET’S CLEAN MACHINES Dan Leblanc Jacksonville 682234 2015 04 22
Robichaud Appliance Repair Philippe Robichaud Saint-Louis 682236 2015 04 22
VU22 PHOTOGRAPHY Andrew McNamara Fredericton 682241 2015 04 22
Intelli Needleless & Dental Solutions Natasha van Loggerenberg Dieppe 682242 2015 04 22
RVCS-RECREATIONAL VEHICLE CONSIGNMENT SERVICES
Peter Mossman Lincoln 682243 2015 04 22
Mariam Writes Mariam Mesbah Moncton 682244 2015 04 22
And It’s Styled by Dawn Dawn Daigle-Simpson Riverview 682247 2015 04 22
Mia’s Business Services High Pressure Washing
Victor Fagan Dieppe 682250 2015 04 22
LUTES LOGGING Lonny Lutes Monteagle 682251 2015 04 22
AC Event Productions Chantelle Elliott New Bandon 682260 2015 04 22
DEL All Seasons Powersports Dan Pethick Belledune 682261 2015 04 22
Boom Lift Rental Plus Andre Boucher Saint-Léonard 682262 2015 04 22
Atlantida Organic Cleaning Anna Petrova Dieppe 682271 2015 04 23
Produits Monacad Products Mario Robichaud Moncton 682290 2015 04 23
_____________________________________________________
PHIL’S AUTO PHIL’S AUTO & RECREATIONSALES, SERVICE & RENTALSLTD.
Lincoln 316874 2015 04 21
UNINSURED AUTOMOBILE FUND/FOND DE NON-ASSURANCE DES TIERS
Facility Association Fredericton 322845 2015 04 21
MONCTON REALITY THERAPY CONSULTANTS
Maureen McIntosh Riverview 325349 2015 04 20
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of renewal of businessname has been registered:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re-nouvellement d’appellation commerciale a été enregistré :
Registrant of Address of Business ReferenceCertificate or Agent Number DateEnregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour
The Royal Gazette — May 13, 2015 599 Gazette royale — 13 mai 2015
ALLGREEN LAWNCARE SERVICES
ALLGREEN LANDSCAPE & DESIGN LTD.
McLeod Hill 330741 2015 04 20
DANA’S COLLISION CENTER DAN-CAR ENTERPRISES INC. Fredericton 338520 2015 04 21
Bill’s Horn Shop William Cosman Moncton 346124 2015 04 21
AQUA AIDE Bernard A. Boucher Shediac River 348880 2015 04 16
GENERAL MILLS CANADA General Mills CanadaCorporation CorporationGeneral Mills Canada
Saint John 601165 2015 04 17
RPT Solutions Randal Torpe Oromocto 616970 2015 04 20
D & R Medical Education Ray Hubble Quispamsis 617163 2015 04 21
FAST MONEY BY NUTTERS DOUWIN GROUP INC. Hampton 617371 2015 04 21
GE HEALTHCARE GENERAL ELECTRIC CANADA/GENERALEELECTRIQUE DU CANADA
Saint John 618149 2015 04 21
SMALL PLANET FOODS General Mills CanadaCorporation CorporationGeneral Mills Canada
Saint John 618512 2015 04 17
The Doggy Den Nancy Brown Fredericton 619244 2015 04 23
A.P. Cole Construction André Paul Cole Fredericton 619935 2015 04 16
Vision Plus DRE. RACHEL LANDRY C.P.INC.
Moncton 647704 2015 04 20
Léo Paul Cormier Auto Body Léo Paul Cormier Lakeville 648988 2015 04 20
Armoires Boudreau Cabinets Andre Boudreau Petit-Rocher-Ouest 649372 2015 04 20
ALISON STREET WEB DESIGN Mark Savidant Lakeside 649383 2015 04 16
Simply Country Treasures Chantal Thériault Grand-Sault / Grand Falls 649669 2015 04 23
O.K. TIRE & AUTO SERVICE (OAK BAY)
633784 N.B. LTD. Oak Bay 649692 2015 04 22
RED’S GREENS NURSERY Kristina Norrad Basswood Ridge 649759 2015 04 20
Uhl Electrical Enterprises Garry Uhl Riverview 649837 2015 04 20
ROYAL LEPAGE Grand Falls Real Estate
GRAND FALLS REAL ESTATELTD.
Grand-Sault / Grand Falls 649927 2015 04 21
Rockhill Enterprises Trevor Douglas Francis Browns Flat 650034 2015 04 21
Sattva Studio Rhonda Carter Miramichi 650077 2015 04 23
Body Renewal Health Centre Julie Piercey Fredericton 650580 2015 04 19
SWAROVSKI LIGHTING Swarovski Lighting, Ltd. Saint John 650636 2015 04 20
Newell Rubbermaid Canada NEWELL INDUSTRIES CANADA INC.
Fredericton 650759 2015 04 21
Newell Rubbermaid Office Products NEWELL INDUSTRIES CANADA INC.
Fredericton 650760 2015 04 21
Hewitt Wildlife Services Christopher Hewitt Upper Lock Lomond 650884 2015 04 22
Credit Depot King Mazda Inc. Saint John 651691 2015 04 17
HOBART FOOD EQUIPMENT GROUP CANADA
ITW CANADA INC. Saint John 655577 2015 04 16
The Royal Gazette — May 13, 2015 600 Gazette royale — 13 mai 2015
HOBART CANADA ITW CANADA INC. Saint John 655579 2015 04 16
ITW CONSTRUCTION PRODUCTS ITW CANADA INC. Saint John 655580 2015 04 16
_____________________________________________________
McSweeney Company Dinner Theatre Moncton 608143 2015 04 16
GE Commerical Finance Fleet Services Saint John 618572 2015 04 21
Projects Plus Rothesay 621900 2015 04 16
HILLSBOROUGH GOLF CLUB Hillsborough 651961 2015 04 17
Oldcastle Building Products Canada/Les Materiaux de Construction Oldcastle Canada
Saint John 653727 2015 04 21
Nashwaak Valley ATV Club Richibucto 657372 2015 04 10
Integra Business Solutions Cocagne 664805 2015 04 16
Aulac Tobacco Shop Aulac 666879 2015 04 15
Brookfield Johnson Controls Canada Saint John 671331 2015 04 17
Brookfield Johnson Controls Saint John 671332 2015 04 17
BO-STYLE MEUBLES ET DÉCO Beresford 680405 2015 04 13
_____________________________________________________
BO-STYLE Meubles et Déco Nancy GuitardPaul Vienneau
Beresford 681640 2015 04 13
JoLi’s Quilting Joanne GirouardLinda Girouard
Moncton 681823 2015 04 01
Coy Wolf Bistro Restaurant Sarah EvansAlan Barbour
Sackville 682042 2015 04 13
Atlas Property Maintenance Andrew HacheyDusty Rothwell
Douglas 682047 2015 04 13
CRAFTOLOGY SJ Sue KingsleyJane M. Stevely
Saint John 682073 2015 04 14
The CASM Group Catherine D. SimpsonMichael W. Alexander
Rothesay 682163 2015 04 17
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of cessation of busi-ness or use of business name has been registered:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de cessa-tion de l’activité ou de cessation d’emploi de l’appellation com-merciale a été enregistré :
ReferenceNumber Date
Address / Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Adresse référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of partnership hasbeen registered:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de so-ciété en nom collectif a été enregistré :
Address of Business Referenceor Agent Number DateAdresse du commerce Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Partners / Membres ou du représentant référence année mois jour
The Royal Gazette — May 13, 2015 601 Gazette royale — 13 mai 2015
Ryles Local Market Léon LeBlancRyan Valiguette
Dieppe 682164 2015 04 17
Droit Dieppe Aubin Peters/Dieppe Law Aubin Peters
Martin AubinNelson J. Peters
Dieppe 682168 2015 04 21
Island Eavestrough Michael L. IngallsJaap Bokkers
Grand Manan 682190 2015 04 20
_____________________________________________________
SALON ELITE St. George 630197 2015 04 14
MAT Trading Limited Partnership King Lord Ltd. Saint John 682108 2015 04 16
Kingsley Townhouses Limited Partnership
Kingsley Townhouses Inc. Fredericton 682170 2015 04 17
_____________________________________________________
BROOKFIELD GLOBAL INTEGRATED SOLUTIONS CANADA LP/BROOKFIELD SOLUTIONS GLOBALES INTÉGRÉES CANADA S.E.C.
Saint John Ontario Stewart McKelveyCorporate Services(NB) Inc.Saint John
400470 2015 04 17
CI Private Counsel LP Saint John Manitoba Stewart McKelveyCorporate Services(NB) Inc.Saint John
623442 2015 04 20
_____________________________________________________
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of dissolution of part-nership has been registered:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de disso-lution de société en nom collectif a été enregistré :
ReferenceNumber Date
Address / Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Adresse référence année mois jour
Loi sur les sociétés en commanditeLimited Partnership Act
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-ship Act, a declaration of limited partnership has been filed by:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de société en commandite a été déposée par :
Principal place in ReferenceNew Brunswick Number Date
General Partners Principal établissement au Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Commandités Nouveau-Brunswick référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-ship Act, a declaration of extra-provincial limited partnership hasbeen filed:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de société en commandite extraprovinciale a été dépo-sée par :
Principal place in ReferenceNew Brunswick Agent and Address Number DatePrincipal établissement au Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Nouveau-Brunswick Compétence et adresse référence année mois jour
The Royal Gazette — May 13, 2015 602 Gazette royale — 13 mai 2015
Brookfield Global Integrated Solutions Canada LP/Brookfield Solutions Globales Intégrées Canada S.E.C.
Brookfield Johnson Controls Canada LP/Brookfield Contrôles Johnson Canada S.E.C.
Ontario Stewart McKelveyCorporate Services(NB) Inc.Saint John
400470 2015 04 17
_____________________________________________________
FRONT STREET FLOW-THROUGH 2013-I LIMITED PARTNERSHIP/SOCIÉTÉ EN COMMANDITE ACCRÉDITIVE FRONT STREET 2013-I
Ontario Arthur T. DoyleSaint John
667379 2015 04 14
FRONT STREET FLOW-THROUGH 2013-II LIMITED PARTNERSHIP/SOCIÉTÉ EN COMMANDITE ACCRÉDITIVE FRONT STREET 2013-II
Ontario Arthur T. DoyleSaint John
672648 2015 04 14
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-ship Act, a declaration of extra-provincial limited partnership,which includes a name change, has been filed:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de société en commandite extraprovinciale, contenantune nouvelle raison sociale, a été déposée par :
ReferenceAgent and Address Number Date
Previous Name Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Ancienne raison sociale Compétence et adresse référence année mois jour
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-ship Act, a declaration of withdrawal of extra-provincial limitedpartnership has been filed:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de retrait de société en commandite extraprovinciale aété déposée par :
ReferenceAgent and Address Number Date
Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence et adresse référence année mois jour
Public notice of change of registered nameunder the Change of Name Act, chapter 103, ss.10(2)
of the Revised Statutes of New Brunswick, 2014
Previous Registered Name: Daniel Joseph Roger AlainDesharnais
New Registered Name: Dani Gabrielle DesharnaisAddress: Dieppe, NBDate Granted: January 26, 2015
Previous Registered Name: Annika Layne KristensenNew Registered Name: Aleksander Erhard KristensenAddress: Miramichi, NBDate Granted: February 7, 2015
Previous Registered Name: Charlotte Renee ZingraffNew Registered Name: Catherine Charlotte Renée
ZingraffAddress: Saint John, NBDate Granted: February 14, 2015
Previous Registered Name: Marc Bertin St-PierreNew Registered Name: Marc BertinAddress: Dieppe, NBDate Granted: February 19, 2015
Service New Brunswick
Avis public de changement de noms enregistrés enapplication de la Loi sur le changement de nom, lois
révisées du Nouveau-Brunswick de 2014, c.103, par.10(2)
Ancien nom enregistré : Daniel Joseph Roger AlainDesharnais
Nouveau nom enregistré : Dani Gabrielle DesharnaisAdresse : Dieppe (N.-B.)Date d’accueil de la demande : Le 26 janvier 2015
Ancien nom enregistré : Annika Layne KristensenNouveau nom enregistré : Aleksander Erhard KristensenAdresse : Miramichi (N.-B.)Date d’accueil de la demande : Le 7 février 2015
Ancien nom enregistré : Charlotte Renee ZingraffNouveau nom enregistré : Catherine Charlotte Renée
ZingraffAdresse : Saint John (N.-B.)Date d’accueil de la demande : Le 14 février 2015
Ancien nom enregistré : Marc Bertin St-PierreNouveau nom enregistré : Marc BertinAdresse : Dieppe (N.-B.)Date d’accueil de la demande : Le 19 février 2015
Services Nouveau-Brunswick
The Royal Gazette — May 13, 2015 603 Gazette royale — 13 mai 2015
AVIS DE RÈGLEL’établissement de l’Instruction générale canadienne 25-201relative aux indications à l’intention des agences de conseil envote (« l’Instruction générale canadienne »).
Approbation de la CommissionLe 23 février 2015, la Commission des services financiers et desservices aux consommateurs a donné son approbation à l’éta-blissement de l’Instruction générale canadienne.
Résumé des modificationsL’instruction générale canadienne fournit des indications auxagences de conseil en vote en matière de pratiques et de com-munication de l’information aux fins suivantes : i) favoriser latransparence de la formulation des recommandations de vote etl’élaboration des lignes directrices en matière de vote par pro-curation, et ii) aider les participants au marché à comprendre lesactivités des agences de conseil en vote.L’instruction générale canadienne traite des points suivants :
• la détermination, la gestion et l’atténuation des conflitsd’intérêts réels ou potentiels;
• la transparence et l’exactitude des recommandations devote;
Ancien nom enregistré : Benjamin Michael HyslopNouveau nom enregistré : Benjamin Michael HughesAdresse : Norton (N.-B.)Date d’accueil de la demande : Le 20 février 2015
Ancien nom enregistré : Gary Francis George RickettsNouveau nom enregistré : Gary Francis George DuretteAdresse : Saint John (N.-B.)Date d’accueil de la demande : Le 24 février 2015
Ancien nom enregistré : Richard Andrew RathboneParsons
Nouveau nom enregistré : Richmal Annabel RathboneParsons
Adresse : West Quaco (N.-B.)Date d’accueil de la demande : Le 26 février 2015
Ancien nom enregistré : Lana Marie HonkeNouveau nom enregistré : Lana Marie MurphyAdresse : Dieppe (N.-B.)Date d’accueil de la demande : Le 27 février 2015
Ancien nom enregistré : Kevin Allie AlvinWafer Legacy
Nouveau nom enregistré : Kevin LegacyAdresse : Bathurst (N.-B.)Date d’accueil de la demande : Le 27 février 2015
Josée DubéRegistraire générale des statistiques
de l’état civil
Commission des services financiers et des services
aux consommateurs
NOTICE OF RULEThe making of National Policy 25-201 Guidance for Proxy Ad-visory Firms (“the Policy”).
Commission ApprovalOn 23 February 2015, the Financial and Consumer ServicesCommission approved the making of the Policy.
Summary of AmendmentsThe Policy provides guidance on recommended practices anddisclosure for proxy advisory firms. The guidance contained inthe Policy is intended to (i) promote transparency in the pro-cesses leading to vote recommendations and the developmentof proxy voting guidelines; and (ii) foster understanding amongmarket participants about the activities of proxy advisory firms.
The Policy addresses the following areas:• identification, management and mitigation of actual or
potential conflicts of interest;• transparency and accuracy of vote recommendations;
Previous Registered Name: Benjamin Michael HyslopNew Registered Name: Benjamin Michael HughesAddress: Norton, NBDate Granted: February 20, 2015
Previous Registered Name: Gary Francis George RickettsNew Registered Name: Gary Francis George DuretteAddress: Saint John, NBDate Granted: February 24, 2015
Previous Registered Name: Richard Andrew RathboneParsons
New Registered Name: Richmal Annabel RathboneParsons
Address: West Quaco, NBDate Granted: February 26, 2015
Previous Registered Name: Lana Marie HonkeNew Registered Name: Lana Marie MurphyAddress: Dieppe, NBDate Granted: February 27, 2015
Previous Registered Name: Kevin Allie AlvinWafer Legacy
New Registered Name: Kevin LegacyAddress: Bathurst, NBDate Granted: February 27, 2015
Josée DubéRegistrar General of Vital Statistics
Financial and Consumer Services Commission
The Royal Gazette — May 13, 2015 604 Gazette royale — 13 mai 2015
• development of proxy voting guidelines;
• communications with clients, market participants, otherstakeholders, the media and the public.
Effective DateThe National Policy came into force in New Brunswick on30 April 2015.
How to Obtain a CopyThe text of the Policy can be obtained from the Commission’swebsite: http://www.fcnb.ca
Paper copies may be obtained from the Commission by writing,telephoning or e-mailing:
SecretaryFinancial and Consumer Services Commission85 Charlotte Street, Suite 300Saint John, N.B. E2L 2J2Telephone: 506-658-3060Toll Free: 866-933-2222 (within NB only)Fax: 506-658-3059E-mail: [email protected]
Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)
To: Doris Ann Allain, original Mortgagor, and to all otherswhom it may concern. Sale pursuant to terms of the Mortgageand the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Acts in amend-ment thereof. Freehold property being situated at 267-269 Uni-versity Avenue, Moncton, New Brunswick, the same lot con-veyed to Doris Ann Allain by Transfer registered in the LandTitles Office on June 15, 2009, as document number 27283531.
Notice of Sale given by Bank of Montreal. Sale to be held atMoncton City Hall located at 655 Main Street, Moncton, NewBrunswick, on the 28th day of April, 2015, at the hour of 11:00a.m., local time. See advertisement of Notice of Sale in theTimes & Transcript dated April 29, May 6, May 13 and May 20,2015.
McInnes Cooper, Solicitors for Bank of Montreal, Per: AdelGönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite S400, P.O.Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6, Telephone:506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095
________________
Notices of Sale
• l’élaboration de lignes directrices en matière de vote parprocuration;
• la communication avec les clients, les participants aumarché, les autres parties prenantes, les médias et lepublic.
Date d’entrée en vigueurL’Instruction générale canadienne est entrée en vigueur auNouveau-Brunswick le 30 avril 2015.
Comment obtenir un exemplaireOn trouvera le texte de l’Instruction générale canadienne par l’en-tremise du site web de la Commission : http://www.fcnb.ca
On peut se procurer un exemplaire sur papier en communiquantpar courrier, par téléphone ou par courriel avec la Commission,dont voici les coordonnées :
SecrétaireCommission des services financiers et des services aux consommateurs85, rue Charlotte, bureau 300Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2J2Téléphone : 506-658-3060Sans frais : 1-866-933-2222 (au N.-B. seulement)Télécopieur : 506-658-3059Courriel : [email protected]
Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, c.S-2, par.1(2)
Destinataires : Doris Ann Allain, débitrice hypothécaire origi-naire; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuée en vertudes dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles de la Loi surles biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Biens en tenure libre situés au267-269, avenue de l’Université, à Moncton (Nouveau-Brunswick), correspondant au même lot ayant été transféré àDoris Ann Allain par l’acte de transfert enregistré au bureau del’enregistrement foncier le 15 juin 2009, sous le numéro27283531.Avis de vente donné par la Banque de Montréal. La vente auralieu le 28 avril 2015, à 11 h, heure locale, à l’hôtel de ville deMoncton, 655, rue Main, Moncton (Nouveau-Brunswick). Voirl’annonce publiée dans les éditions du 29 avril et des 6, 13 et20 mai 2015 du Times & Transcript.
Adel Gönczi, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Banquede Montréal, Centre de la Croix Bleue, bureau S400, 644, rueMain, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6;téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506-857-4095
________________
Avis de vente
The Royal Gazette — May 13, 2015 605 Gazette royale — 13 mai 2015
Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)
To: Mikelle Anita Thibodeau, Mortgagor and owner of the eq-uity of redemption; and to all others whom it may concern. Saleunder the terms of the mortgage and the Property Act, R.S.N.B.1973, c.P-19. Freehold property situate at 142 Lac Road,Memramcook, Province of New Brunswick, the said land cor-responding to the same lot having been conveyed to MikelleAnita Thibodeau by deed registered at the Land Registry Officeas Number 20144268.
Notice of Sale given by the Bank of Nova Scotia, Mortgagee.Sale on May 28, 2015, at 11:15 a.m., local time, at MonctonCity Hall, 655 Main Street, Moncton, New Brunswick. See no-tice of sale in the April 29, May 6, May 13, and May 20, 2015,editions of L’Acadie Nouvelle.
McInnes Cooper, Solicitors for the Bank of Nova Scotia, perAdel Gönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite S400,P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick E1C 8T6, telephone:506-857-8970, fax: 506-857-4095
________________
Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)
To: Krystal Kaye Pyne, original Mortgagor and the owner of theequity of redemption; and to all others whom it may concern.Sale pursuant to terms of the mortgage and the Property Act,R.S.N.B. 1973, c.P-19, as amended. Freehold property situate at6753 Route 116, Harcourt, in the County of Kent and Provinceof New Brunswick, and being identified as PID 25242561.
Notice of Sale given by The Toronto-Dominion Bank, Mort-gagee and holder of the first mortgage. Sale to be held at theBouctouche Town Hall, 30 Evangeline Street, Bouctouche,N.B. on Thursday, May 21, 2015, at the hour of 11:00 a.m., localtime. See advertisement of Notice of Mortgage Sale in theTimes & Transcript dated April 23, April 30, May 7, and May14, 2015.
McInnes Cooper, Solicitors for The Toronto-Dominion Bank,Per: R. Scott Wilson, Suite 1700, Brunswick Square, 1 GermainStreet, P.O. Box 6370, Saint John, New Brunswick, E2L 4R8,Telephone: 506-643-6500, Facsimile: 506-643-6505
________________
Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)
To: Derek Paul Mathers, original Mortgagor and owner of theequity of redemption; and to all others whom it may concern.Sale pursuant to terms of the mortgage and the Property Act,R.S.N.B. 1973, c.P-19, as amended. Freehold property situate at464 Bartholomew Road, Blackville, in the County of Northum-berland and Province of New Brunswick, and being identifiedas PID 40375040.
Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, c.S-2, par.1(2)
Destinataire : Mikelle Anita Thibodeau, débiteur hypothécaireet propriétaire du droit de rachat, et tout autre intéressé éventuel.Vente effectuée conformément aux dispositions de l’acte d’hy-pothèque et de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Bienen tenure libre situé au 142, chemin Lac, Memramcook, pro-vince du Nouveau-Brunswick, ledit bien correspondant aumême lot ayant été transféré à Mikelle Anita Thibodeau parTransfert enregistré au bureau d’enregistrement foncier sous lenuméro 20144268.Avis de vente donné par La Banque de Nouvelle-Écosse, créan-cière hypothécaire. La vente aura lieu le 28 mai 2015 à 11 h 15,heure locale, à l’Hôtel de ville de Moncton, situé au 655, rueMain, Moncton (Nouveau-Brunswick). Voir l’avis de vente pu-blié dans les éditions L’Acadie Nouvelle du 29 avril, 6 mai,13 mai et 20 mai 2015.
McInnes Cooper, avocats de La Banque de Nouvelle-Écosse,par Adel Gönczi, Centre Croix Bleue, 644, rue Main, PièceS400, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6,téléphone : 506-857-8970, télécopieur : 506-857-4095
________________
Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, c.S-2, par.1(2)
Destinataire : Krystal Kaye Pyne, débitrice hypothécaire origi-naire et propriétaire du droit de rachat; et tout autre intéressééventuel. Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acted’hypothèque et de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19.Biens en tenure libre situés au 6753, route 116, à Harcourt,comté de Kent, province du Nouveau-Brunswick, et dont leNID est 25242561.Avis de vente donné par la Banque Toronto-Dominion, créan-cière hypothécaire et titulaire de la première hypothèque. Lavente aura lieu le jeudi 21 mai 2015, à 11 h, heure locale, à l’hô-tel de ville de Bouctouche, 30, rue Évangéline, Bouctouche(Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditionsdes 23 et 30 avril et des 7 et 14 mai 2015 du Times & Transcript.
R. Scott Wilson, du cabinet McInnes Cooper, avocats de laBanque Toronto-Dominion, Brunswick Square, bureau 1700,1, rue Germain, C.P. 6370, Saint John (Nouveau-Brunswick)E2L 4R8; téléphone : 506-643-6500; télécopieur : 506-643-6505
________________
Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, c.S-2, par.1(2)
Destinataire : Derek Paul Mathers, débiteur hypothécaire origi-naire et propriétaire du droit de rachat; et tout autre intéressééventuel. Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acted’hypothèque et de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19.Biens en tenure libre situés au 464, chemin Bartholomew, àBlackville, comté de Northumberland, province du Nouveau-Brunswick, et dont le NID est 40375040.
The Royal Gazette — May 13, 2015 606 Gazette royale — 13 mai 2015
Notice of Sale given by The Toronto-Dominion Bank, Mort-gagee and holder of the mortgage. Sale to be held at theMiramichi Court House, 673 King George Highway,Miramichi, New Brunswick on Thursday, May 21, 2015, at thehour of 11:00 a.m., local time. See advertisement of Notice ofMortgage Sale in the Miramichi Leader dated April 22, April29, May 6 and May 13, 2015.
McInnes Cooper, Solicitors for The Toronto-Dominion Bank,Per: Natalie M. Stewart, Suite 1700, Brunswick Square,1 Germain Street, P.O. Box 6370, Saint John, New Brunswick,E2L 4R8, Telephone: 506-643-6500, Facsimile: 506-643-6505
________________
To: Sandra Marie Panneton, 125 St-Amateur Road, Trudel,Gloucester County and Province of New Brunswick, Mort-gagor;AND TO: ALL OTHERS WHOM IT MAY CONCERN.Freehold premises situate, lying and being among others at125 St-Amateur Road, in Trudel, Gloucester County and Prov-ince of New Brunswick known as PID 20113247.NOTICE OF SALE given by la Caisse Populaire de Shippa-gan Limitée as first Mortgagee by virtue of the power of salecontained in the mortgage and the Property Act.
Sale to be held on the May 27, 2015, at 11:00 a.m., at the en-trance of the Municipal Building of the Town of Caraquet, lo-cated at 10 Du Colisée Street, in Caraquet, in the County ofGloucester, New Brunswick.See advertisement in the newspaper L’Acadie Nouvelle, edi-tions of April 29, May 6, May 13, and May 20, 2015.
JONATHAN ROCH NOËL, Solicitor for la Caisse Populaire deShippagan Limitée
________________
TO: ACADIA MARBLE, TILE & TERRAZZO LTD. (OriginalMortgagor and Owner of the Equity of Redemption);MICHAEL LEO DiVALENTIN (Mortgage Holder);CANADA REVENUE AGENCY (Judgment Creditor); andANGLO ELECTRIC (1981) LTD. (Claimant); AND ALLOTHERS WHOM IT MAY CONCERN.
TAKE NOTICE that default having been made in payment ofthe monies secured under a collateral mortgage dated March 3,2011 and registered in the Sunbury County Land Titles Registryon March 18, 2011 as number 29907210 (the “Mortgage”)given by ACADIA MARBLE TILE & TERRAZZO LTD. tothe ROYAL BANK OF CANADA, for the purpose of securingthe principal indebtedness, interest and other amounts thereindescribed: THERE WILL BE SOLD BY PRIVATE SALE,pursuant to the power of sale conferred by section 44 of theProperty Act, as amended, for purpose of recovering the moniessecured thereby, at the offices of Cox & Palmer, 644 MainStreet, Suite 500, Moncton, New Brunswick, June 2, 2015 at2:00 p.m. local time, those lands and premises being situate at1850 Lincoln Road, in the City of Fredericton, Parish of
Avis de vente donné par la Banque Toronto-Dominion, créan-cière hypothécaire et titulaire de l’hypothèque. La vente auralieu le jeudi 21 mai 2015, à 11 h, heure locale, au palais dejustice de Miramichi, 673, route King George, Miramichi(Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditionsdes 22 et 29 avril et des 6 et 13 mai 2015 du Miramichi Leader.
Natalie M. Stewart, du cabinet McInnes Cooper, avocats de laBanque Toronto-Dominion, Brunswick Square, bureau 1700,1, rue Germain, C.P. 6370, Saint John (Nouveau-Brunswick)E2L 4R8; téléphone : 506-643-6500; télécopieur : 506-643-6505
________________
Destinataire : Sandra Marie Panneton, 125, chemin St-Amateur, Trudel, comté de Gloucester et province du Nouveau-Brunswick, débitrice hypothécaire;ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.Biens en tenure libre étant situé, entre autre, au 125, cheminSt-Amateur, Trudel, dans le comté de Gloucester et province duNouveau-Brunswick et dont le NID est : 20113247.AVIS DE VENTE donné par la Caisse Populaire de Shippa-gan Limitée, titulaire de la première hypothèque en vertu dupouvoir de vente contenu dans l’acte d’hypothèque et de la Loisur les biens.La vente aura lieu le 27 mai 2015, à 11 h à l’entrée de l’Édificemunicipal de la ville de Caraquet, 10, rue du Colisée, àCaraquet, dans le comté de Gloucester, au Nouveau-Brunswick.
Voir l’annonce publiée dans les éditions du 29 avril et du6, 13 et 20 mai 2015 du journal L’Acadie Nouvelle.
JONATHAN ROCH NOËL, avocat pour la Caisse Populaire deShippagan Limitée
________________
DESTINATAIRES : ACADIA MARBLE, TILE & TER-RAZZO LTD. (débitrice hypothécaire originaire et propriétairedu droit de rachat); MICHAEL LEO DiVALENTIN (titulairede l’hypothèque); AGENCE DU REVENU DU CANADA(créancière sur jugement); ANGLO ELECTRIC (1981) LTD.(demanderesse); ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVEN-TUEL.SACHEZ QU’étant donné le défaut de paiement des sommesgaranties par l’hypothèque subsidiaire établie le 3 mars 2011entre ACADIA MARBLE, TILE & TERRAZZO LTD. et laBANQUE ROYALE DU CANADA, ladite hypothèque ayantété enregistrée au registre des titres fonciers du comté deSunbury le 18 mars 2011, sous le numéro 29907210(« l’hypothèque »), SERONT VENDUS PAR VENTE PRI-VÉE, en vertu du pouvoir de vente conféré par l’article 44 de laLoi sur les biens, aux fins d’obtenir le paiement des sommes ga-ranties par ladite hypothèque et de garantir le remboursementdu capital, des intérêts et des autres montants qui y sont décrits,au cabinet Cox & Palmer, situé au 644, rue Main, bureau 500,Moncton (Nouveau-Brunswick), le 2 juin 2015, à 14 h, heurelocale, le terrain et les bâtiments situés au 1850, chemin
The Royal Gazette — May 13, 2015 607 Gazette royale — 13 mai 2015
Lincoln, County of Sunbury, Province of New Brunswick (PIDs60000007, 60116696 and 60116688) together with all buildingsand rights associated therewith.
DATED this 28th day of April, A.D. 2015.
ROYAL BANK OF CANADAper its solicitors
Cox & Palmer, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite 500,Moncton, NB E1C 1EC, Tel: 506-863-0793, Fax: 506-856-8150
The Royal Gazette is published every Wednesday under theauthority of the Queen’s Printer Act. Documents must be re-ceived by the Royal Gazette Coordinator, LegislativeServices, no later than noon, at least seven days prior toWednesday’s publication. Each document must be separatefrom the covering letter. Signatures on documents must be im-mediately followed by the printed name. The Royal GazetteCoordinator may refuse to publish a document if any part of itis illegible, and may delay publication of any document for ad-ministrative reasons.Prepayment is required for the publication of all documents.Standard documents have the following set fees:
NoticesCost perInsertion
Notice of the intention to apply for the enactment of a private bill
$ 20
Originating process $ 25Order of a court $ 25Notice under the Absconding Debtors Act $ 20Notice under the General Rules under the Law Society Act,
1996, of disbarment or suspension or of application forreinstatement or readmission
$ 20
Notice of examination under the Licensed Practical NursesAct
$ 25
Notice under the Motor Carrier Act $ 30Any document under the Political Process Financing Act $ 20
Notice to creditors under New Brunswick Regulation 84-9under the Probate Court Act
$ 20
Notice under Rule 70 of the Rules of CourtNote: Survey Maps cannot exceed 8.5″ x 14″
$120
Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is1/2 page in length or less
$ 20
Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice isgreater than 1/2 page in length
$ 75
Any document under the Winding-up and Restructuring Act(Canada)
$ 20
Notice to Advertisers
Lincoln, à Fredericton, paroisse de Lincoln, comté de Sunbury,province du Nouveau-Brunswick (NID 60000007, 60116696 et60116688), ainsi que tous les bâtiments et droits qui y sontassociés.FAIT le 28 avril 2015.
LA BANQUE ROYALE DU CANADApar son avocat
Cox & Palmer, Centre de la Croix Bleue, bureau 500, 644, rueMain, Moncton (N.-B.) E1C 1EC; téléphone : 506-863-0793,télécopieur : 506-856-8150
La Gazette royale est publiée tous les mercredis conformé-ment à la Loi sur l’Imprimeur de la Reine. Les documents àpublier doivent parvenir à la coordonnatrice de la Gazetteroyale, aux Services législatifs, à midi, au moins sept joursavant le mercredi de publication. Chaque avis doit être séparéde la lettre d’envoi. Les noms des signataires doivent suivreimmédiatement la signature. La coordonnatrice de la Gazetteroyale peut refuser de publier un avis dont une partie est illi-sible et retarder la publication d’un avis pour des raisons ad-ministratives.Le paiement d’avance est exigé pour la publication des avis.Voici les tarifs pour les avis courants :
AvisCoût par parution
Avis d’intention de demander l’adoption d’un projet de loid’intérêt privé
20 $
Acte introductif d’instance 25 $Ordonnance rendue par une cour 25 $Avis exigé par la Loi sur les débiteurs en fuite 20 $Avis de radiation ou de suspension ou de demande de
réintégration ou de réadmission, exigé par les Règlesgénérales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur leBarreau
20 $
Avis d’examen exigé par la Loi sur les infirmières etinfirmiers auxiliaires autorisés
25 $
Avis exigé par la Loi sur les transports routiers 30 $Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur le
financement de l’activité politique20 $
Avis aux créanciers exigé par le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-9 établi en vertu de la Loi sur la Cour dessuccessions
20 $
Avis exigé par la Règle 70 des Règles de procédureNota : Les plans d’arpentage ne doivent pas dépasser 8,5 po
sur 14 po
120 $
Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voied’annonces, si l’avis est d’une demi-page ou moins enlongueur
20 $
Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voied’annonces, si l’avis est de plus d’une demi-page enlongueur
75 $
Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur lesliquidations et les restructurations (Canada)
20 $
Avis aux annonceurs
The Royal Gazette — May 13, 2015 608 Gazette royale — 13 mai 2015
Payments can be made by cash, MasterCard, VISA, cheque ormoney order (payable to the Minister of Finance). No refundswill be issued for cancellations.
The official version of The Royal Gazette is available freeon-line each Wednesday. This free on-line service replaces theprinted annual subscription service. The Royal Gazette can beaccessed on-line at:
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/attorney_general/royal_gazette.html
Print-on-demand copies of The Royal Gazette are available, atthe following address, at $4.00 per copy plus 5% tax, plusshipping and handling where applicable.
Legislative ServicesOffice of the Attorney General
Chancery Place675 King StreetP.O. Box 6000
Fredericton, NB E3B 5H1
Tel: 506-453-8372E-mail: [email protected]
Note: Deliveries are to be addressed to The Royal Gazette andleft with the Commissionaire.
Notice of a correction charge isthe same as
for publishing the original document
Any other document $3.50 for each cm or less
Les paiements peuvent être faits en espèces, par carte decrédit MasterCard ou VISA, ou par chèque ou mandat (àl’ordre du ministre des Finances). Aucun remboursement nesera effectué en cas d’annulation.
La version officielle de la Gazette royale est disponible gra-tuitement et en ligne chaque mercredi. Ce service gratuit enligne remplace le service d’abonnement annuel. Vous trouve-rez la Gazette royale à l’adresse suivante :
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/procureur_general/gazette_royale.html
Nous offrons, sur demande, des exemplaires de la Gazetteroyale, à l’adresse suivante, pour la somme de 4 $ l’exem-plaire, plus la taxe de 5 %, ainsi que les frais applicables deport et de manutention.
Services législatifsCabinet du procureur général
Place Chancery675, rue King
C.P. 6000Fredericton (N.-B.) E3B 5H1
Tél. : 506-453-8372Courriel : [email protected]
Note : Toute livraison étant adressée à la Gazette royale doitêtre remise au commissionnaire.
Avis d’une correction les frais sont les mêmes que ceux imposés
pour la publication du
document original
Tout autre document 3,50 $ pour chaque cm ou
moins
QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK
All rights reserved / Tous droits réservés